주메뉴 바로가기
본문 바로가기(skip to content)
퀵메뉴 바로가기
마이메뉴 바로가기
도서관정보 바로가기
글로벌메뉴
주메뉴
이용안내
신청방법
저널목록
인기 학술지
원문검색
CNU Search
RISS Search
ScienceON Search
FRIC Search
신청내역
관리자 목록
센터소개
소개
연혁
운영시간
조직
게시판
센터소식
이용문의
자료실
이용안내
신청방법
저널목록
인기 학술지
원문검색
CNU Search
RISS Search
NDSL Search
FRIC Search
신청내역
센터소개
소개
연혁
운영시간
조직
게시판
센터소식
이용문의
자료실
CNU Search
|
Home
>
원문검색
>
CNU Search
>
가나다리스트
탭메뉴
기본검색
가나다리스트
전체
ㅣ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
ㅣ
가
나
다
라
마
바
사
아
자
차
카
타
파
하
기타
검색 타입
전체
서명
저자
발행처
ISSN
수록DB
키워드
전방일치
완전일치
결과내 검색
검색어
[가나다ABC : L]
총
1,574
건 중
1,574
건 출력
72/79
페이지
제한항목
단행본
검색결과제한
자료유형
단행본
(1574)
저자
이재철
(25)
백광훈
(21)
이재철 著
(20)
이준현
(16)
백광훈 편저
(14)
이준현 편저
(12)
메가로스쿨 언어논리연구소
(11)
메가로스쿨 언어논리연구소 지음
(11)
언어논리연구소
(11)
Freeman, Michael D. A
(9)
Sarat, Austin
(7)
Dimond, Bridgit
(6)
Jasper, Margaret C
(6)
Webb, Julian S
(6)
Bossche, Peter van den
(5)
Douglas, Lawrence
(5)
Sloan, Irving J
(5)
Umphrey, Martha Merrill
(5)
Adams, Alix
(4)
Aspatore, Inc
(4)
Center for Studies and Research
(4)
Cooter, Robert
(4)
Greer, Sarah
(4)
Hague Academy of International Law Center for Studies and Research
(4)
Hamilton, Robert W. 1931-
(4)
더보기
(20)
more...
더보기 취소
출판사
Oxford University Press
(202)
Cambridge University Press
(106)
Nomos
(45)
Sweet & Maxwell
(38)
Thomson
(37)
West
(37)
Kluwer Law International
(27)
윌비스
(25)
Routledge
(24)
Ashgate
(23)
Foundation Press
(22)
Peter Lang
(21)
Butterworths
(20)
LexisNexis
(20)
Aspen Publishers
(15)
Nolo
(15)
Oceana Publications
(15)
Springer
(15)
박문각
(15)
Hart
(14)
West Pub. Co
(14)
Edward Elgar
(12)
메가로스쿨
(12)
Carolina Academic Press
(11)
Harvard University Press
(11)
Martinus Nijhoff Publishers
(11)
더보기
(20)
more...
더보기 취소
발행년도
2008
(160)
2007
(140)
2011
(137)
2010
(126)
2009
(120)
2006
(118)
2005
(103)
2004
(55)
2012
(55)
2003
(45)
2013
(36)
2002
(27)
2014
(27)
2001
(25)
2019
(21)
2017
(17)
2018
(17)
1994
(14)
2020
(14)
2022
(14)
1983
(13)
1986
(13)
1987
(13)
2016
(13)
1975
(11)
더보기
(20)
more...
더보기 취소
언어
영어
(1257)
한국어
(137)
독어
(113)
불어
(46)
일본어
(8)
소장처
법학도서관
(1574)
중앙도서관
(29)
검색간략리스트
항목선택
서명
저자
발행처
원문제공시작년
정렬
오름차순
내림차순
5
10
15
20
30
50
100
1421.
서명
Lords of the land : indigenous property rights and the jurisprudence of empire
저자
Mark Hickford
발행처
Oxford University Press
원문제공시작년
2011
자료유형
단행본
원문복사 신청
원문제공마감년
1422.
서명
L'originalité de la responsabilité du fait des dommages de travaux publics
저자
Jean-Philippe Ferreira ; préface de Fabrice Melleray
발행처
Dalloz
원문제공시작년
2020
자료유형
단행본
원문복사 신청
원문제공마감년
1423.
서명
Losing twice:harms of indifference in the Supreme Court
저자
Emily M. Calhoun
발행처
Oxford University Press
원문제공시작년
2011
자료유형
단행본
원문복사 신청
원문제공마감년
1424.
서명
Loss of control and diminished responsibility:domestic, comparative and international perspectives
저자
edited by Alan Reed and Michael Bohlander
발행처
Ashgate Pub.
원문제공시작년
2011
자료유형
단행본
원문복사 신청
원문제공마감년
1425.
서명
Loss of housekeeping capacity
저자
Ernst Karner, Ken Oliphant (eds.) ; with contributions by Bjarte Askeland ... [et al.]
발행처
De Gruyter
원문제공시작년
2012
자료유형
단행본
원문복사 신청
원문제공마감년
1426.
서명
The lost history of the Ninth Amendment
저자
Kurt T. Lash
발행처
Oxford University Press
원문제공시작년
2009
자료유형
단행본
원문복사 신청
원문제공마감년
1427.
서명
Losungsklauseln und Insolvenz
저자
Sven Wortberg
발행처
Peter Lang
원문제공시작년
2003
자료유형
단행본
원문복사 신청
원문제공마감년
1428.
서명
Louisiana Civil Code 2016: as revised and amended through the 2015 regular session of the legislature
저자
edited by A. N. Yiannopoulos
발행처
Thomson Reuters
원문제공시작년
2016
자료유형
단행본
원문복사 신청
원문제공마감년
1429.
서명
Louisiana civil code : with official legislative commentary
저자
Melissa T. Lonegrass
발행처
West Adacemic
원문제공시작년
2025
자료유형
단행본
원문복사 신청
원문제공마감년
1430.
서명
Louisiana code of civil procedure : as amended through the 2013 Regular Session of the Legislature
저자
edited by William E. Crawford
발행처
Thomson/West
원문제공시작년
2014
자료유형
단행본
원문복사 신청
원문제공마감년
1431.
서명
Louisiana Code of Civil Procedure: as amended through the 2015 regular session of the legislature
저자
edited by William E. Crawford
발행처
Thomson Reuters
원문제공시작년
2016
자료유형
단행본
원문복사 신청
원문제공마감년
1432.
서명
Louisiana family law in comparative perspective
저자
Elizabeth R. Carter, A.N. Yiannopoulos Professor of Law, Judge Anthony J. Graphia & Jo Ann Graphia Professor of Law, Louisiana State University, Pau
발행처
Carolina Academic Press
원문제공시작년
2018
자료유형
단행본
원문복사 신청
원문제공마감년
1433.
서명
Louisiana law of obligations : a methodological & comparative perspective cases, texts and materials
저자
Alain A. Levasseur, Randall Trahan, Sandi Varnado ; with the assistance of Katherine Hand
발행처
Carolina Academic Press
원문제공시작년
2013
자료유형
단행본
원문복사 신청
원문제공마감년
1434.
서명
Louisiana law of obligations : a methodological & comparative perspective cases, texts and materials
저자
Alain A. Levasseur, Nikolaos A. Davrados, J. Randall Trahan, Sandi Varnado
발행처
Carolina Academic Press
원문제공시작년
2023
자료유형
단행본
원문복사 신청
원문제공마감년
1435.
서명
Love, power, and justice : ontological analyses and ethical applications
저자
Paul Tillich
발행처
Oxford University Press
원문제공시작년
1976
자료유형
단행본
원문복사 신청
원문제공마감년
1436.
서명
Lower taxes in 7 easy steps
저자
by Steven Fishman
발행처
Nolo
원문제공시작년
2006
자료유형
단행본
원문복사 신청
원문제공마감년
1437.
서명
Lower your taxes-big time!
저자
by Sandy Botkin
발행처
McGraw-Hill
원문제공시작년
2007
자료유형
단행본
원문복사 신청
원문제공마감년
1438.
서명
Lower your taxes-big time!:wealth-building, tax reduction secrets from an IRS insider
저자
Sandy Botkin
발행처
McGraw-Hill
원문제공시작년
2003
자료유형
단행본
원문복사 신청
원문제공마감년
1439.
서명
Lower your taxes--big time!:wealth-building, tax reduction secrets from an IRS insider.2011/2012
저자
Sandy Botkin
발행처
McGraw-Hill
원문제공시작년
2011
자료유형
단행본
원문복사 신청
원문제공마감년
1440.
서명
Lowe's transport manager's & operator's handbook.2012
저자
David Lowe
발행처
Kogan Page
원문제공시작년
2012
자료유형
단행본
원문복사 신청
원문제공마감년
71
72
73
74
75
76
77
78
79
임시보관함보기
하단메뉴